Ontario Gazette Volume 148 Issue 02, La Gazette de l'Ontario

Vol. 148-02
Saturday, 10 January 2015
Toronto
ISSN 00302937
Le samedi 10 janvier 2015
Parliamentary Notice
Avis parlementaire
Royal Assent
Sanction royale
THE PROVINCE OF ONTARIO
PROVINCE DE L’ONTARIO
Toronto, Thursday, December 4, 2014, 2:10 p.m.
Toronto, jeudi, 4 décembre, 2014, 14 h 10.
In the name of Her Majesty the Queen, Her Honour the Lieutenant
Governor, assented to the following bill in her office:-
Au nom de Sa Majesté la Reine, Son Honneur la lieutenante-gouverneure,
a accordé la sanction royale au projet de loi suivant, dans son bureau:-
Bill 10
(148-G004E)
An Act to enact the Child Care and Early Years
Act, 2014, to repeal the Day Nurseries Act, to
amend the Early Childhood Educators Act,
2007, the Education Act and the Ministry of
Training, Colleges and Universities Act and to
make consequential and related amendments
to other Acts.
[S.O. 2014, Chapter 11]
Projet de loi 10 Loi édictant la Loi de 2014 sur la garde
d’enfants et la petite enfance, abrogeant la Loi
sur les garderies, modifiant la Loi de 2007 sur
les éducatrices et les éducateurs de la petite
enfance, la Loi sur l’éducation et la Loi sur
le ministère de la Formation et des Collèges
et Universités et apportant des modifications
corrélatives et connexes à d’autres lois.
[L.O. 2014, Chapitre 11]
Deborah Deller
Clerk of the Legislative Assembly
La greffière de l’Assemblée législative
Deborah Deller
(148-G004F)
Royal Assent
Sanction royale
THE PROVINCE OF ONTARIO
PROVINCE DE L’ONTARIO
Toronto, Thursday, December 11, 2014, 2:20 p.m.
Toronto, jeudi, 11 décembre, 2014, 14 h 20.
In the name of Her Majesty the Queen, Her Honour the Lieutenant
Governor, assented to the following bills in her office:-
Au nom de Sa Majesté la Reine, Son Honneur la lieutenante-gouverneure,
a accordé la sanction royale aux projets de loi suivant, dans son bureau:-
Bill 7
An Act to enact the Burden Reduction
Reporting Act, 2014 and the Partnerships for
Jobs and Growth Act, 2014.
[S.O. 2014, Chapter 12]
Projet de loi 7
Bill 8
An Act to promote public sector and MPP
accountability and transparency by enacting
the Broader Public Sector Executive
Compensation Act, 2014 and amending
various Acts.
[S.O. 2014, Chapter 13]
Projet de loi 8
Published by Ministry of Government Services
Publié par le ministère des Services gouvernementaux
Loi édictant la Loi de 2014 sur l’obligation
de faire rapport concernant la réduction des
fardeaux administratifs et la Loi de 2014 sur
les partenariats pour la création d’emplois et
la croissance.
[L.O. 2014, Chapitre 12]
Loi visant à promouvoir la responsabilisation
et la transparence du secteur public et des
députés par l’édiction de la Loi de 2014 sur la
rémunération des cadres du secteur parapublic
et la modification de diverses lois.
[L.O. 2014, Chapitre 13]
© Queen’s Printer for Ontario, 2015
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015
161
162
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Bill 21
An Act to safeguard health care integrity by
enacting the Voluntary Blood Donations Act,
2014 and by amending certain statutes with
respect to the regulation of pharmacies and
other matters concerning regulated health
professions.
[S.O. 2014, Chapter 14]
Projet de loi 21
An Act to repeal the Public Works Protection
Act, amend the Police Services Act with
respect to court security and enact the Security
for Electricity Generating Facilities and
Nuclear Facilities Act, 2014.
[S.O. 2014, Chapter 15]
Projet de loi 35
Bill Pr1
An Act respecting The Loretto Ladies’
Colleges and Schools.
[S.O. 2014, Chapter Pr6]
An Act respecting The Loretto Ladies’
Colleges and Schools.
[S.O. 2014, Chapter Pr6]
Bill Pr2
An Act to revive 1474486 Ontario Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr7]
Bill Pr2
An Act to revive 1474486 Ontario Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr7]
Bill Pr3
An Act to revive Bensfort Wood Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr8]
Bill Pr3
An Act to revive Bensfort Wood Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr8]
Bill Pr4
An Act to revive Bruno’s Alignment Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr9]
Bill Pr4
An Act to revive Bruno’s Alignment Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr9]
Bill Pr5
An Act respecting Bible Baptist Temple (St.
Thomas).
[S.O. 2014, Chapter Pr10]
Bill Pr5
An Act respecting Bible Baptist Temple (St.
Thomas).
[S.O. 2014, Chapter Pr10]
Bill Pr6
An Act respecting The Macdonald Stewart
Community Art Centre.
[S.O. 2014, Chapter Pr11]
An Act respecting The Macdonald Stewart
Community Art Centre.
[S.O. 2014, Chapter Pr11]
Bill Pr8
An Act respecting Saint Paul University.
[S.O. 2014, Chapter Pr12]
Bill Pr8
An Act respecting Saint Paul University.
[S.O. 2014, Chapter Pr12]
Bill Pr9
An Act to revive 1807041 Ontario Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr13]
Bill Pr9
An Act to revive 1807041 Ontario Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr13]
Bill Pr10
An Act to revive 752458 Ontario Ltd.
[S.O. 2014, Chapter Pr14]
Bill Pr10
An Act to revive 752458 Ontario Ltd.
[S.O. 2014, Chapter Pr14]
Bill Pr11
An Act to revive 469118 Ontario Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr15]
Bill Pr11
An Act to revive 469118 Ontario Limited.
[S.O. 2014, Chapter Pr15]
Bill Pr12
An Act to revive 658055 Ontario Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr16]
Bill Pr12
An Act to revive 658055 Ontario Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr16]
Bill Pr13
An Act to revive Walker Towne Centre Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr17]
Bill Pr13
An Act to revive Walker Towne Centre Inc.
[S.O. 2014, Chapter Pr17]
Bill 35
Bill Pr1
Bill Pr6
Deborah Deller
Clerk of the Legislative Assembly
(148-G005E)
Loi visant à sauvegarder l’intégrité des soins
de santé par l’édiction de la Loi de 2014 sur
le don de sang volontaire et la modification
de certaines lois en ce qui concerne la
réglementation des pharmacies et d’autres
questions relatives aux professions de la santé
réglementées.
[L.O. 2014, Chapitre 14]
Loi abrogeant la Loi sur la protection des
ouvrages publics, modifiant la Loi sur les
services policiers en ce qui concerne la
sécurité des tribunaux et édictant la Loi de
2014 sur la sécurité des centrales électriques
et des installations nucléaires.
[L.O. 2014, Chapitre 15]
La greffière de l’Assemblée législative
Deborah Deller
(148-G005F)
Criminal Code
Code Criminel
DESIGNATION OF QUALIFIED TECHNICIANS
(BREATH SAMPLES)
NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to subsection 254(1) of
the Criminal Code (Canada), the Honourable Jim Bradley, Minister of
Community Safety and Correctional Services of Ontario, on the 9th day
of August, 2011, designated the following persons as being qualified to
operate the approved instruments known as the Intoxilyzer® 8000C.
L’AVIS PRESENT est donné qu’en vertu du paragraphe 254(1) du Code
Criminel du Canada, 1’honourable Jim Bradley, Ministre de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario, le 9 Août, 2011,
désigna les personnes suivantes comme étant qualifiées pour manipuler les
alcootest approuvé connu sous de nom de Intoxilyzer® 8000C.
Aaron Fraser
Chris Johnson
Christopher Graham
Craig Murray
Greg Bryant
Kim Manuel
Kyle Johnstone
Lucas Cummings
Matthew Lobsinger
Michelle McIntyre
Richard Veerman
Scott Hindley
Sean James
Steve Bogart
Tim Pinder
Travis Sandham
(148-G006)
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
Strathroy-Caradoc Police Service
Woodstock Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
Strathroy-Caradoc Police Service
London Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
St. Thomas Police Service
Woodstock Police Service
St. Thomas Police Service
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO163
Ontario Highway Transport Board
Periodically, temporary applications are filed with the Board. Details of
these applications can be made available at anytime to any interested
parties by calling (416) 326-6732.
The following are applications for extra-provincial and public vehicle
operating licenses filed under the Motor Vehicle Transport Act, 1987,
and the Public Vehicles Act. All information pertaining to the applicant
i.e. business plan, supporting evidence, etc. is on file at the Board and is
available upon request.
Any interested person who has an economic interest in the outcome of
these applications may serve and file an objection within 29 days of this
publication. The objector shall:
1. complete a Notice of Objection Form,
4. pay the appropriate fee.
Serving and filing an objection may be by hand delivery, mail, courier or
facsimile. Serving means the date received by a party and filing means the
date received by the Board.
LES LIBELLÉS DÉS DEMANDES PUBLIÉES CI-DESSOUS SONT
AUSSI DISPONIBLES EN FRANÇAIS SUR DEMANDE.
Pour obtenir de l’information en français, veuillez communiquer avec la
Commission des transports routiers au 416-326-6732.
9068244 Canada Limited
47616 & 47616-A
1 Howard Avenue, St. Catharines, ON L2N 3W8
Applies for the approval of transfer of extra provincial operating licence
X-3847 and public vehicle operating licence PV-5712, both now in the
name of Charter Bus Ontario Inc., 8074 Biggar Road, Port Robinson,
Ontario L0S 1K0.
2. serve the applicant with the objection,
3. file a copy of the objection and provide proof of service of the objection
on the applicant with the Board,
(148-G007)
Felix D’mello
Board Secretary/Secrétaire de la Commission
Government Notices Respecting Corporations
Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Notice of Default in Complying
with the Corporations Tax Act
Avis de non-observation de la Loi sur
l’imposition des sociétés
The Director has been notified by the Minister of Finance that the
following corporations are in default in complying with the Corporations
Tax Act.
NOTICE IS HEREBY GIVEN under subsection 241(1) of the Business
Corporations Act, that unless the corporations listed hereunder comply
with the requirements of the Corporations Tax Act within 90 days of this
notice, orders will be made dissolving the defaulting corporations. All
enquiries concerning this notice are to be directed to Ministry of Finance,
Corporations Tax, 33 King Street West, Oshawa, Ontario L1H 8H6.
Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes
n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.
AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément au
paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés
citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par
la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant
la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par
décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous
adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King
ouest, Oshawa ON L1H 8H6.
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
2015-01-10
ADVANCED ENERGY SERVICES INCORPORATED
001194298
AFFLICTION CLOTHING CANADA INC.
002122570
AKRAM INTERNATIONAL INC.
002005786
ALEXANDER INSURANCE BROKERS LTD.
002121379
ALLICORP INVESTMENTS INCORPORATED
002057100
B N B CARTAGE INC.
001705861
BAR DE LATOUR CORPORATION
002071116
BAYERN TRUCKING INC.
001643079
BDSM PHOENIX MANUFACTURING INC.
001691627
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
BLUE JAY PACKING SERVICE INC.
001297289
BROWNSTONE CONSULTING GROUP INC.
002072557
CAKES, ETC. LTD.
000981316
CAMBODIAN EMPLOYMENT AGENCY INC.
001676458
CAN AM DEVELOPMENTS INC.
000749665
CAPITAL FINANCE CORP.
002069791
CONSULTING JACQUARD INC.
001148166
DAVID GARDNER SOUND & LIGHTING INC.
001466170
DCDG DEVELOPMENT INC.
002058387
DIGITAL HI-END INC.
001001957
DOSEN RENOVATIONS LTD.
002135037
EQUIGENESIS 2005 PREFERRED INVESTMENT GP II
CORP.
002081673
ERSHA MANAGEMENT INC.
002123224
FARR LUMBER LTD.
000942303
GERANIUM HOMES (COBOURG) LTD.
000802193
GLOBAL PHARMACEUTICAL & BROKER
INCORPORATED
002068462
GORE GROCERY INC.
002053674
GRAY WOLF CAPITAL CORPORATION
001640531
GREEN FOOTPRINT E-WASTE SOLUTIONS INC.
002161386
HINGSON FINANCIAL CORPORATION
001677659
HOME & CITY MAGAZINE INC.
001155684
INSTARACK INSTALLATIONS LTD.
000544511
J HAJCMAN LIMITED
000365173
JEWISH CONNECTIONS INC.
001214878
K.LANDRY CONTRACTING INC.
001738147
KESHAVAYA INC.
002098724
KIDS LOVE HOCKEY INC.
001138310
KRYSTAL CLEAR COMMUNICATIONS INC.
000946965
LONGLAST ELECTRICAL INDUSTRIES LTD.
000409417
MARGARET MA & ASSOCIATES INC.
001003197
MT. ALBERT INVESTMENT CORPORATION
000886028
MTA CONTRACTING INC.
002021055
NANUA HOLDING INC.
001158544
NETMAX TECHNOLOGIES INC.
002073594
NG INTERNATIONAL INC.
001707958
NORTH BRIDGE CAPITAL MANAGEMENT (CANADA)
INC.
002151983
164
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
NUSTRIDE CORPORATION
001562081
OLYMPIC STAR MASONRY LTD.
001094937
ONEIDA OF THE THAMES MARKETING LIMITED
000695784
PATTEN THAT QUILT INC.
001435580
PROMAR TILE INC.
001698127
PYN POINT SALES INC.
001328742
QUALTEC CORPORATION
001490783
RAMAC INC.
001325100
RED TRIANGLE DEVELOPMENTS INC.
000815045
SCIENTIFIC DIMENSIONS INC.
000977608
SHING FAT HING INTERNATIONAL TRADING INC.
002147423
SHOWMAX INC.
001696796
SMARTEGG LEGACY LTD.
001179559
SMARTLUNCH INC.
001670376
SOUTHERN GEORGIAN BAY CONTRACTING
CORPORATION
001646472
SUTLEJ FOREIGN EXCHANGE INC.
002078428
TE-EM CONSULTING INC.
002071477
THE CONTINUUM NETWORK INC.
001634480
THORNHILL ACOUSTICS & CONSTRUCTION LIMITED 000297657
TIMES FINE CARS INC.
001261168
UPITER CONSULTING & CONSTRUCTION INC.
001478676
URUCAN FINANCIAL SERVICES INC.
001672506
VYNAKOR WINDOWS INC.
000809021
WASAE INC.
002135016
YOU’RE BEAUTIFUL INC.
002097354
1004809 ONTARIO INC.
001004809
1020692 ONTARIO INC.
001020692
1023536 ONTARIO LTD.
001023536
1036268 ONTARIO INC.
001036268
1070844 ONTARIO LIMITED
001070844
1137192 ONTARIO INC.
001137192
1159326 ONTARIO LIMITED
001159326
1184880 ONTARIO INC.
001184880
1232380 ONTARIO INC.
001232380
1235055 ONTARIO INC.
001235055
1278558 ONTARIO INC.
001278558
1302635 ONTARIO LIMITED
001302635
1344815 ONTARIO INC.
001344815
1382780 ONTARIO INC.
001382780
1394744 ONTARIO INC.
001394744
1396419 ONTARIO LTD.
001396419
1475431 ONTARIO INC.
001475431
1486547 ONTARIO INC.
001486547
1511675 ONTARIO INC.
001511675
1543977 ONTARIO LIMITED
001543977
1611100 ONTARIO LTD.
001611100
1640229 ONTARIO LTD
001640229
1647375 ONTARIO LIMITED
001647375
1658395 ONTARIO CORPORATION
001658395
1659690 ONTARIO INC.
001659690
1662762 ONTARIO INC.
001662762
1684412 ONTARIO INC.
001684412
1703312 ONTARIO LTD.
001703312
1733115 ONTARIO INC.
001733115
1734003 ONTARIO INC.
001734003
1735130 ONTARIO LIMITED
001735130
1753682 ONTARIO LTD.
001753682
1758487 ONTARIO INC.
001758487
2043639 ONTARIO INC.
002043639
2051563 ONTARIO LTD.
002051563
2074429 ONTARIO INC.
002074429
2082883 ONTARIO INC.
002082883
Name of Corporation:
Dénomination sociale
de la société :
2085067 ONTARIO LTD.
2115926 ONTARIO CORPORATION
2124013 ONTARIO LTD.
2124032 ONTARIO INC.
2130953 ONTARIO LTD.
2131191 ONTARIO LTD.
2141126 ONTARIO INC.
2147061 ONTARIO INC.
648188 ONTARIO INC.
663225 ONTARIO LIMITED
704017 ONTARIO LIMITED
749421 ONTARIO INC
940493 ONTARIO INC.
(148-G008)
Ontario Corporation Number
Numéro de la
société en Ontario
002085067
002115926
002124013
002124032
002130953
002131191
002141126
002147061
000648188
000663225
000704017
000749421
000940493
William D. Snell
Director, Ministry of Government Services
Directeur, Ministère des Services
gouvernementaux
Cancellation of Certificate of Incorporation
(Corporations Tax Act Defaulters)
Annulation de certificat de
constitution (Non-observation de la
Loi sur l’imposition des sociétés)
NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under subsection 241(4) of the
Business Corporations Act, the Certificate of Incorporation of the
corporations named hereunder have been cancelled by an Order for default
in complying with the provisions of the Corporations Tax Act, and the said
corporations have been dissolved on that date.
AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément au
paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de
constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour nonobservation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que
la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
2014-12-15
“REEL” FUN INC.
001136255
A.M.G. INVESTMENTS INC.
002121295
ALLIED EXTERIORS INC.
001517203
ANALYSIS SYNTHESIS CONSULTING
INCORPORATED
000858790
BANGKOK HOUSE INC.
002156184
BEVIN-ANDREW HOLDINGS 2005 INC.
001635578
BOTA HERBAL LTD.
001716615
C. J. WAGSTAFF & ASSOCIATES INSURANCE
BROKERS LTD.
000333977
CANADA-RENTALS INC.
001397491
CANADIAN COLONIAL FURNITURE LTD.
001319226
CAPPOLA FAMILY HOLDINGS LTD.
001152351
CASI CARPENTRY LTD.
001623142
CASSINI SECOND HAND DEALERSHIP INC.
001259130
CHARMERS CAFE LTD.
000743759
CITATECH INC.
001534924
CIVIC AUTOS INC.
001107070
COOL SCENTS CORPORATION
001325088
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO165
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
CRIME INTERVENTION & ASSOCIATES
CONSULTANTS INC.
001112864
DESIGN REHAB INC.
001721458
DESIGN VARIATION INC.
001136468
DZD CANADA INC.
002050990
ERIC MCCULLOUGH LIMITED
000405209
ETERNA FOOD SERVICE LTD.
001001340
EVERYTHING & MORE LTD.
001276931
EXCALIBUR WOOD MANUFACTURING INC.
001441309
FASKEN INTERNATIONAL CORPORATION
000663832
FLUVIAS GENERAL CONTRACTING LTD.
000619878
FORMULA X RACER INC.
001232748
FRIENDLY SUPERMARKET CORP.
001503524
FURNISHING COMFORT LTD.
000972712
FURNISHINGS FOR HOME AND BUSINESS INC.
001139927
GROSVENOR FLOWERS 1989 INC.
000854834
IDEAL PACKAGING PRODUCTS INC.
001404706
INCORPORATED MERCHANT CAPITAL PARTNERS
001275952
J. TEICH AND CO. LTD.
000302061
KAREN GOBIN PROFESSIONAL CORPORATION
002128052
KELDIGITAL INC.
002111573
KINETICIS INC.
001662205
KITCHEN ROOTS LIMITED
001463862
LATIN AMERICAN MINING INVESTMENT CORP.
001183044
MCKNIGHT’S HAULAGE & EXCAVATORS LIMITED
000099436
MINOS TO GO INC.
002111327
MRKR INVESTMENTS LTD.
001244964
PLANT APPRAISERS & LIQUIDATORS LIMITED
000331580
PREMIUM HOUSE GARMENT PRINTERS LIMITED
001076861
PRO-CUSTOM JANITORIAL INC.
001408091
QG PUBLISHING INC.
001427968
RHONDA R. HOWARD DISPLAY LTD.
000676776
ROSI’S DELI-CAFE BAKERY AND BANQUET PLACE
LTD.
000892633
SOMEBUDDY’S CLEANING & RESTORATION
SERVICES INC.
000927212
SPG STRUCTURAL PANELS GROUP INC.
000974021
STEEL TECHNOLOGIES FRAMING INC.
001335793
SUPERIOR ROLLER HOCKEY LEAGUE INC.
002118522
TERRY FORLER AUTOMOTIVE LTD.
001159412
TFGI (SHELBURNE 2) INC.
002122720
THE ABBAS GROUP INC.
000651520
THE ARCHIPELAGO GROUP INC.
000708579
THE CAUSEWAY RESTAURANT LTD.
001178904
THE IMAGE DEPARTMENT INC.
001639092
TORONTO GOLF SCRAMBLE INC.
001726809
TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS CONSULTING
INC.
000631784
TREE TOP CUSTOM HOME BUILDERS INC.
002105011
TUTTI FRUITTI HOLDINGS INC.
001521997
WEBFLARE COMMUNICATIONS INC.
002110493
WILLIAMSFORD FEED MILL COMPANY LIMITED
000248176
WORLD BUSINESS MACHINES LIMITED
000350239
WORLD GEM INTERNATIONAL CANADA LTD.
002106274
1018971 ONTARIO INC.
001018971
1033359 ONTARIO LIMITED
001033359
1073872 ONTARIO LIMITED
001073872
1075357 ONTARIO INC.
001075357
1079211 ONTARIO INC.
001079211
1083817 ONTARIO LIMITED
001083817
1099212 ONTARIO LTD.
001099212
1106304 ONTARIO LTD.
001106304
1168539 ONTARIO INC.
001168539
1171935 ONTARIO LIMITED
001171935
1173671 ONTARIO LTD
001173671
1190955 ONTARIO INC.
001190955
1199446 ONTARIO INC.
001199446
Name of Corporation:
Dénomination sociale
de la société :
1228119 ONTARIO INC.
1298748 ONTARIO INC.
1324768 ONTARIO INC.
1353830 ONTARIO INC.
1361081 ONTARIO LTD.
1383786 ONTARIO INC.
1389837 ONTARIO INC.
1424448 ONTARIO LIMITED
1496719 ONTARIO INC.
1607580 ONTARIO INC.
1660537 ONTARIO LIMITED
1668551 ONTARIO LTD.
1671006 ONTARIO INC.
1679957 ONTARIO LTD.
1693941 ONTARIO INC.
1747132 ONTARIO LIMITED
2109013 ONTARIO LIMITED
2113393 ONTARIO INC.
2155243 ONTARIO INC.
504919 ONTARIO INC.
594520 ONTARIO INC.
637874 ONTARIO LTD.
659208 ONTARIO INC.
676740 ONTARIO LTD.
686782 ONTARIO INC.
705838 ONTARIO INCORPORATED
717984 ONTARIO LIMITED
775457 ONTARIO INC.
791599 ONTARIO LIMITED
826555 ONTARIO INC.
838041 ONTARIO INC.
913343 ONTARIO LIMITED
970372 ONTARIO LTD.
981638 ONTARIO LIMITED
983324 ONTARIO INC.
(148-G009)
Ontario Corporation Number
Numéro de la
société en Ontario
001228119
001298748
001324768
001353830
001361081
001383786
001389837
001424448
001496719
001607580
001660537
001668551
001671006
001679957
001693941
001747132
002109013
002113393
002155243
000504919
000594520
000637874
000659208
000676740
000686782
000705838
000717984
000775457
000791599
000826555
000838041
000913343
000970372
000981638
000983324
William D. Snell
Director, Ministry of Government Services
Directeur, Ministère des Services
gouvernementaux
Certificate of Dissolution
Certificat de dissolution
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a certificate of dissolution under the
Business Corporations Act, has been endorsed. The effective date of
dissolution precedes the corporation listings.
AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément à la Loi
sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour
les compagnies suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des
compagnies visées.
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
2014-11-28
ALI HUSEIN DRUGS LTD.
001185818
CARRIER TRUCK & TRAILER REPAIR LTD.
002083372
CASTELLO BROTHERS INC.
002321339
CHIMAX SYSTEMS INC.
002120634
DBE FOOD EQUIPMENT INC. DBE EQUIPEMENT
ALIMENTAIRE INC.
000555357
GREG CARDUCCI CONSULTING INC.
000629367
HSE COMPLIANCE INC.
002257849
166
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
JACKRYN FRANCE INC.
002036232
KNISH & CO. DELI INC.
001355772
NICK SKRYPEC HOLDINGS LIMITED
000214777
S.O.A.R. MUSKOKA INC.
001886421
SMN DRUGS LIMITED
002087306
TOTAL MOTORWORX INC.
002293367
1413487 ONTARIO LIMITED
001413487
1460823 ONTARIO INC.
001460823
2169697 ONTARIO LIMITED
002169697
581999 ONTARIO LIMITED
000581999
836930 ONTARIO INC.
000836930
2014-12-01
BILDON ENTERPRISES INC.
001696887
COTTAGE COUNTRY CONSTRUCTION LTD.
001405200
NASSER HOLDINGS INC.
001685298
POTTER TECHNICAL SERVICES INC.
001574945
STEWART OUTSOURCED SALES INC.
002303035
THERMOVOLT TECHNOLOGY LIMITED
000506167
1881198 ONTARIO INC.
001881198
2014-12-02
AROUND THE CLOCK TRANSPORT INC.
002070002
DAVIDSON FARMS LIMITED
000231851
LOTUS GARDEN RESTAURANT AND TAVERN (1997)
INC.
001242347
TECHNOLOGIESV INC.
002328368
1523534 ONTARIO INC.
001523534
2047991 ONTARIO LIMITED
002047991
2014-12-03
AL PRO SERVICE INC.
001490414
BETTER BLINDS AND DRAPES WINDSOR INC.
001081289
CORROSION DIAGNOSTICS LTD.
001257559
CYBERBRAKE AUTO PARTS INC.
002236456
FLOORS BY CALEY LTD.
000689979
H&H ENGINEERING, SCIENCE AND RESEARCH INC. 002160458
KOFA INTERNATIONAL LTD.
000586154
LA RESTAURANT GROUP INC.
001858157
LEAN MANUFACTURING SOLUTIONS INC.
001371638
MARCONDA DEVELOPMENT CORPORATION
000631684
MORNING SUN SOFTWARE DEVELOPMENT INC.
001612348
NEAR NORTH SAFETY & COMPLIANCE SERVICES INC. 001427748
QUADRANT CONSULTING SERVICES INC.
001412709
RUSSELL DERRAH ASSOCIATES INC.
001539538
SEN COMMUNICATIONS INC.
001460818
SHULIST HOLDINGS INC.
002105382
SOISSA LTD.
001664555
SUN VOLTS UNLIMITED INC.
000933036
T & T MARBLE GRANITE CORPORATION
001579735
TASTE OF THAILAND CORP.
002052403
1456156 ONTARIO INC.
001456156
2077519 ONTARIO INC.
002077519
2254808 ONTARIO INC.
002254808
477497 ONTARIO LIMITED
000477497
672395 ONTARIO INC.
000672395
833326 ONTARIO INC.
000833326
2014-12-06
1021431 ONTARIO LIMITED
001021431
2014-12-16
R.S. & S. OLIVER ENTERPRISES INC.
000239628
2014-12-17
GREASE BUSTER RESTAURANT GREASE TRAP
CLEANING INC.
002308423
THUNDER BAY METIS ECONOMIC DEVELOPMENT
CORPORATION
002264469
1514608 ONTARIO INC.
001514608
1633824 ONTARIO INC.
001633824
2014-12-18
DELTA SHIPPING INTERNATIONAL INC.
001370746
Name of Corporation:
Ontario Corporation Number
Dénomination sociale
Numéro de la
de la société :
société en Ontario
DICKY DECORATION INC.
001158718
FIBERLAND LTD.
002351834
HOMEIMAGE INC.
002282039
I-SHINE MAINTENANCE & CLEANING SYSTEMS INC. 002341606
JINNIU HUITONG TRADING INC.
002295052
LONDON EXECUTIVE CONSULTANTS INC.
000476667
LUXCORP CONTRACTING INC.
002268972
MACRO TRANSLATIONS INC.
001720273
MC RENOVATION & HOME IMPROVEMENT INC.
002311767
MEMOIRS 11 LTD.
002299761
MISSISSAUGA EXECUTIVE CONSULTANTS INC.
001307893
NORTHLAND POWER SOLAR CLUSTER ONE INC.
001876910
NORTHLAND POWER SOLAR CLUSTER TWO INC.
001876911
R. KOSKI TRUCKING INC.
000636896
ROYAL ROOFING GROUP INC.
001822970
TORONTO EXECUTIVE CONSULTANTS INC.
000482576
WINART.CA LTD.
001648788
1479097 ONTARIO INC.
001479097
1813516 ONTARIO LTD.
001813516
890213 ONTARIO LTD.
000890213
2014-12-19
ACTTL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
001491874
APPEL LTD.
001095952
BELL & BOB TRANSPORT LTD.
002028217
BURRO PARALEGAL CORP.
001157386
CROMBIE TANNER INVESTMENTS LTD.
000829463
HORSE DREEEMZ INCORPORATED
002236631
MARINO CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
000073198
OAKLAND HOLDINGS LIMITED
000465763
REICH ENTERPRISES INC.
000924946
TRISECT SURVEYS LTD.
001848851
VAL CARON COLLISION CENTRE LTD.
001264181
WOLCAN INTERNATIONAL CORP.
002305724
1266933 ONTARIO LTD.
001266933
1648107 ONTARIO LTD.
001648107
2047345 ONTARIO LIMITED
002047345
2159803 ONTARIO INC.
002159803
2325189 ONTARIO INC.
002325189
2014-12-22
ALTUS GROUP LATIN AMERICA INC.
002274998
FEET FOR LIFE SCHOOL OF PODIATRIC NURSING INC. 002417400
HWY 59 SOUTH PROPERTIES INC.
002151375
PENTELIUK FINANCIAL CORPORATION
002062808
SNAB HOLDINGS LIMITED
000257588
T&E STUDIO TANNING & ESTHETICS INC.
001692109
1713996 ONTARIO INC.
001713996
878735 ONTARIO LIMITED
000878735
935292 ONTARIO LIMITED
000935292
2014-12-23
ACE WALL INSTALLATIONS INC.
001606408
AV OFFICE 2007 INC.
001745452
SEFANA INC.
001826865
SOLAJA CONSULTING INC.
001489373
SPARKLE BUILDING SERVICES INC.
001659069
VANILAND INC.
001734169
1214873 ONTARIO LIMITED
001214873
2008130 ONTARIO INC.
002008130
2316768 ONTARIO INC.
002316768
906903 ONTARIO LIMITED
000906903
(148-G010)
William D. Snell
Director, Ministry of Government Services
Directeur, Ministère des Services
gouvernementaux
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO167
Foreign Cultural Objects Immunity from Seizure Act Determination
Pursuant to delegated authority and in accordance with subsection 1(1) of the Foreign Cultural Objects Immunity from Seizure Act, R.S.O. 1990, c.F-23, the
work of art or object of cultural significance listed in Schedule “A” attached hereto, which work or object is to be on temporary exhibit during the Vanishing
Ice: Alpine and Polar landscapes in Art, 1775-2012 exhibition at the McMichael Canadian Art Collection in Kleinburg, Ontario pursuant to a loan agreement
between the McMichael Canadian Art Collection and the lender listed in the attached Schedule “A”, is hereby determined to be of cultural significance and the
temporary exhibition of this work or object in Ontario is in the interest of the people of Ontario.
DATE: December 29, 2014
Determined by Kevin Finnerty, Assistant Deputy Minister
Culture Division
Ministry of Tourism, Culture and Sport
SCHEDULE “A” – LIST OF WORKS
Vanishing Ice: Alpine and Polar landscapes in Art, 1775-2012
McMichael Canadian Art Collection
LENDER
1
ARTIST
National Gallery of Art,
Washington DC
Thomas Hart
Benton
OBJECT
Painting
DATE
1964/1965
MEDIUM
DIMENSIONS INVENTORY NO.
Oil on Canvas
56 1/8 x 74
inches
1975.42.1
(148-G011)
Applications to Provincial
Parliament — Private Bills
Demandes au Parlement provincial —
Projets de loi d’intérêt privé
PUBLIC NOTICE
The rules of procedure and the fees and costs related to applications
for Private Bills are set out in the Standing Orders of the Legislative
Assembly's Internet site at http://www.ontla.on.ca or from:
Procedural Services Branch
Room 1405, Whitney Block, Queen's Park
Toronto, Ontario M7A 1A2
Telephone: 416/325-3500 (Collect calls will be accepted)
Applicants should note that consideration of applications for Private Bills
that are received after the first day of September in any calendar year may be
postponed until the first regular Session in the next following calendar year.
(8699) T.F.N
Deborah Deller,
Clerk of the Legislative Assembly.
Corporation Notices
Avis relatifs aux compagnies
BRAINJUICER CANADA INC.
TAKE NOTICE that the shareholder of BRAINJUICER CANADA
INC. passed a Special Resolution on December 22, 2014 requiring the
said Corporation to be wound up voluntarily under the provisions of the
Business Corporations Act (Ontario).
DATED December 22, 2014.
(148-P005)
James B. Geddes
Secretary
BRAINJUICER CANADA INC.
TAKE NOTICE that a final meeting of the Shareholders of the above
Corporation was held on December 22, 2014, at which time the Liquidator
of the above Corporation presented her account and explanation of the
voluntary winding up of BRAINJUICER CANADA INC.
DATED December 22, 2014.
(148-P006)
James B. Geddes
Liquidator
This page intentionally left blank
Cette page est volontairement laissée en blanc
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO169
Publications under Part III (Regulations) of the Legislation Act, 2006
Règlements publiés en application de la partie III (Règlements)
de la Loi de 2006 sur la législation
2015—01—10
ONTARIO REGULATION 310/14
made under the
ESTATE ADMINISTRATION TAX ACT, 1998
Made: December 22, 2014
Filed: December 22, 2014
Published on e-Laws: December 23, 2014
Printed in The Ontario Gazette: January 10, 2015
INFORMATION REQUIRED UNDER SECTION 4.1 OF THE ACT
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Application of s. 4.1 (1) of the Act
Deemed day of giving return or revised return
Return under s. 4.1 (2) of the Act
Requirement to update information, amended return
Requirement to update information, notify Minister
Additional information, refund received
Additional information, additional tax or deposit
Additional information, undertaking under s. 4 (3) of the Act
Commencement
Application of s. 4.1 (1) of the Act
1. For the purposes of subsection 4.1 (1) of the Act, the prescribed date is January 1, 2015.
Deemed day of giving return or revised return
2. A return or revised return required under this Regulation is deemed to have been given to the Minister on the day on
which it is received by the Minister.
Return under s. 4.1 (2) of the Act
3. (1) Information about a deceased person that is required under subsection 4.1 (2) of the Act must be given to the
Minister by the estate representative, in a return approved by the Minister, no later than 90 days after an estate certificate is
issued to the estate representative.
(2) The return must contain the following information about the deceased person:
1.Name.
2. Address of fixed place of abode.
3. Date of birth or, if not known, the approximate date or year of birth.
4. Date of death.
5. A complete list of the assets of the deceased person used to determine the value of the estate, including the following
information with respect to each asset:
i. The actual value of the asset or, if the actual value is unavailable, the estimated value of the asset at the time of
the deceased person’s death.
ii. If the asset is real property,
A. the full address of the real property, including, where applicable, the street number, street name, street
direction, unit number, rural route number, town or city, and postal code,
B. the actual value of any encumbrances on the real property,
149
170
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
C. the assessment roll number of the real property that is created or used under the Assessment Act, and
D. the property identifier mentioned in subsection 141 (2) of the Land Titles Act or subsection 21 (2) of the
Registry Act, if any, of the real property.
iii. If the asset is cash (including cash on deposit with a Canadian or foreign bank, a broker, a credit union or
caisse populaire, a loan corporation or a trust corporation), a guaranteed investment certificate, a loan receivable,
a security (including common shares, preferred shares, bonds, treasury bills and mutual funds), a contract of
insurance without a named beneficiary, a derivative (including options, futures contracts, rights or warrants), an
interest in a partnership or any other investment, a full description of the asset, including,
A. the type of asset,
B. the number of units held at the time of the deceased person’s death, if applicable,
C. other particulars of the asset, such as the particular series of bonds or the particular class of shares,
D. the name and contact information of the deceased person’s adviser, dealer, financial institution or other
person holding the asset on behalf of the deceased person, if applicable, and
E. the account number in relation to the asset assigned by the person or institution referred to in subsubparagraph D, if applicable.
iv. If the asset is not an asset referred to in subparagraph ii or iii, detailed information about the asset, including the
type of asset and other particulars of the asset.
v. If the deceased person was known by a name that is different than the name set out in paragraph 1 and if the asset
is registered or held under that other name, the asset and the other name of the deceased person.
vi. If the asset is owned by the deceased person as tenant-in-common, the asset and the percentage that is owned by
the deceased person at the time of death.
6. The amount of tax owing or paid under section 2 of the Act by the estate of the deceased person or the amount
deposited under section 3 of the Act by the applicant referred to in that section.
7. The name and contact information of every estate representative of the deceased person.
8. The address of the court where the application for a certificate of appointment of estate trustee was made.
9. The type of application that was made by the estate representative in respect of the estate of the deceased person under
Rule 74.04, 74.05, 74.05.1, 74.08 or 74.09 of the Rules of Civil Procedure.
10. The court file number that is assigned to the application referred to in paragraph 9.
11. The date on which the estate certificate was issued to the estate representative.
12. If the tax or deposit was calculated based on the estimated value of the estate, the date on which the estate representative
gave an undertaking required under subsection 3 (4) of the Act and a copy of the undertaking.
13. If the Superior Court of Justice issued the estate certificate under subrule 74.13 (3) of the Rules of Civil Procedure,
without payment of a deposit required under section 3 of the Act,
i. a copy of the order that was obtained under subsection 4 (1) of the Act, and
ii. details about the security furnished to the court under subsection 4 (2) of the Act.
14. Any other information about the deceased person that is necessary for the determination of the amount of tax owing
or paid under section 2 of the Act.
(3) If any assets described in subparagraph 5 iii of subsection (2) are held by an adviser, dealer, financial institution or
other person on behalf of the deceased person, the return may include the following information about those assets instead of
the information required under subparagraphs 5 i and iii of subsection (2) in respect of those assets:
1. The name and contact information of the adviser, dealer, financial institution or other person who holds those assets.
2. The account number or numbers associated with the adviser, dealer, financial institution or other person in relation to
those assets.
3. The total value of all of the assets within each of the accounts referred to in paragraph 2.
Requirement to update information, amended return
4. (1) If the estate representative becomes aware that any information described in paragraph 5, 6 or 14 of subsection 3 (2)
or in subsection 3 (3) that was given in the return is incorrect or incomplete, the estate representative shall give the Minister
a revised return containing updated information, including the reason for updating the information.
150
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO171
(2) The revised return under subsection (1) must be given no later than 30 days after the estate representative becomes
aware that the information given is incorrect or incomplete.
(3) A revised return under subsection (1) is not required if the estate representative becomes aware of the incorrect or
incomplete information after the fourth anniversary of the day tax became payable.
(4) Despite subsections (1), (2) and (3), if a statement disclosing subsequently discovered property of the estate is delivered
under subsection 32 (2) of the Estates Act, the estate representative shall give the Minister, no later than 30 days after the
statement is delivered, a revised return with particulars about the subsequently discovered property.
Requirement to update information, notify Minister
5. If the estate representative becomes aware that any information described in paragraph 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 or 13
of subsection 3 (2) that was given in the return is incorrect or incomplete, the estate representative shall notify the Minister
in writing of the updated information no later than 30 days after the estate representative becomes aware that the information
given is incorrect or incomplete.
Additional information, refund received
6. If a full or partial refund of a deposit or tax imposed under the Act is received by the estate representative after giving
the return under section 3, the estate representative shall, no later than 30 days after the refund is received, give the Minister
a revised return with particulars about the refund.
Additional information, additional tax or deposit
7. If an additional tax imposed under the Act is paid or an additional amount is deposited by the estate representative after
giving the return under section 3, the estate representative shall, no later than 30 days after the payment or the deposit is
made, give the Minister a revised return with particulars about the payment or amount deposited.
Additional information, undertaking under s. 4 (3) of the Act
8. If the estate representative gives an undertaking described in subsection 4 (3) of the Act with respect to the estate of
the deceased person, the estate representative shall, no later than 30 days after fulfilling the undertaking, give the Minister a
revised return with particulars about the fulfilment of the undertaking and any additional tax paid.
Commencement
9. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2015 and the day it is filed.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: December 22, 2014.
Pris le : 22 décembre 2014.
2/15
151
172
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/14
pris en vertu de la
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS
pris le 22 décembre 2014
déposé le 22 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 10 janvier 2015
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR L’ARTICLE 4.1 DE LA LOI
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Application du par. 4.1 (1) de la Loi
Jour où la déclaration est réputée remise
Déclaration visée au par. 4.1 (2) de la Loi
Obligation de mise à jour des renseignements : déclaration modifiée
Obligation de mise à jour des renseignements : avis au ministre
Renseignements supplémentaires : remboursement reçu
Renseignements supplémentaires : impôt ou dépôt supplémentaire
Renseignements supplémentaires : engagement prévu au par. 4 (3) de la Loi
Entrée en vigueur
Application du par. 4.1 (1) de la Loi
1. Pour l’application du paragraphe 4.1 (1) de la Loi, la date prescrite est le 1er janvier 2015.
Jour où la déclaration est réputée remise
2. Toute déclaration ou déclaration révisée exigée aux termes du présent règlement est réputée avoir été remise au ministre
le jour où il la reçoit.
Déclaration visée au par. 4.1 (2) de la Loi
3. (1) Les renseignements que le paragraphe 4.1 (2) de la Loi exige de remettre au ministre au sujet d’un défunt doivent
être donnés par le représentant successoral dans la déclaration approuvée par le ministre, au plus tard 90 jours après la
délivrance d’un certificat successoral au représentant successoral.
(2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants au sujet du défunt :
1. Le nom.
2. L’adresse de la résidence permanente.
3. La date de naissance ou, si celle-ci n’est pas connue, la date ou l’année approximative de la naissance.
4. La date du décès.
5. La liste complète des biens du défunt qui ont servi à établir la valeur de la succession, y compris les renseignements
suivants concernant chaque bien :
i. La valeur réelle du bien ou, si celle-ci n’est pas connue, sa valeur estimative au moment du décès.
ii. S’il s’agit d’un bien immeuble :
A. l’adresse complète du bien immeuble, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point
cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,
B. la valeur réelle de toute charge qui grève le bien immeuble,
C. le numéro de rôle d’évaluation du bien immeuble qui est créé ou utilisé dans le cadre de la Loi sur
l’évaluation foncière,
D. la cote foncière, mentionnée au paragraphe 141 (2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou
au paragraphe 21 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes, du bien immeuble, le cas échéant.
iii. S’il s’agit de liquidités — notamment des fonds déposés auprès d’une banque canadienne ou étrangère, d’un
courtier, d’une caisse populaire ou d’une credit union, d’une société de prêt ou d’une société de fiducie —,
d’un certificat de placement garanti, d’un prêt, d’une valeur mobilière — notamment des actions ordinaires, des
actions privilégiées, des obligations, des bons du Trésor et des fonds communs de placement —, d’un contrat
152
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO173
d’assurance sans bénéficiaire désigné, d’un dérivé — notamment des options, des contrats à terme, des droits,
des bons de souscription ou des mandats —, d’une participation dans une société de personnes ou de tout autre
placement, une description complète du bien, notamment :
A. le type de bien,
B. le nombre de titres détenus au moment du décès, s’il y a lieu,
C. d’autres précisions concernant le bien, telles que la série d’obligations ou la catégorie d’actions,
D. le nom et les coordonnées du conseiller, du courtier ou de l’institution financière du défunt ou de la personne
qui détient le bien pour le compte du défunt, s’il y a lieu,
E. le numéro de compte se rapportant au bien et attribué par la personne ou l’institution visée à la sous-sousdisposition D, s’il y a lieu.
iv. S’il ne s’agit pas d’un bien mentionné à la sous-disposition ii ou iii, des renseignements détaillés sur le bien,
notamment le type de bien et d’autres précisions concernant le bien.
v. Si le défunt était connu sous un nom autre que celui indiqué à la disposition 1 et que le bien est enregistré ou
détenu sous cet autre nom, le bien dont il s’agit et l’autre nom du défunt.
vi. Si le bien appartient au défunt en qualité de tenant commun, le bien dont il s’agit et le pourcentage qui lui
appartient au moment du décès.
6. Le montant de l’impôt dû ou payé aux termes de l’article 2 de la Loi par la succession du défunt ou le montant déposé
aux termes de l’article 3 de la Loi par le requérant visé à cet article.
7. Le nom et les coordonnées de chaque représentant successoral du défunt.
8. L’adresse du tribunal où a été présentée la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de
la succession.
9. Le type de requête que le représentant successoral a présenté à l’égard de la succession du défunt aux termes de la règle
74.04, 74.05, 74.05.1, 74.08 ou 74.09 des Règles de procédure civile.
10. Le numéro de dossier du tribunal qui est attribué à la requête visée à la disposition 9.
11. La date à laquelle le certificat successoral a été délivré au représentant successoral.
12. Si le calcul du montant de l’impôt ou du dépôt est fondé sur la valeur estimative de la succession, la date à laquelle le
représentant successoral a remis l’engagement exigé au paragraphe 3 (4) de la Loi et une copie de l’engagement.
13. Si la Cour supérieure de justice a délivré le certificat successoral en vertu du paragraphe 74.13 (3) des Règles de
procédure civile, sans avoir reçu le dépôt exigé par l’article 3 de la Loi :
i. une copie de l’ordonnance obtenue en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi,
ii. des précisions sur la garantie fournie au tribunal en application du paragraphe 4 (2) de la Loi.
14. Tout autre renseignement sur le défunt qui est nécessaire pour établir le montant de l’impôt dû ou payé aux termes de
l’article 2 de la Loi.
(3) Si des biens visés à la sous-disposition 5 iii du paragraphe (2) sont détenus par un conseiller, un courtier, une institution
financière ou une autre personne pour le compte du défunt, la déclaration peut comprendre les renseignements suivants
concernant ces biens au lieu des renseignements exigés aux termes des sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (2) à l’égard
de ces biens :
1. Le nom et les coordonnées du conseiller, du courtier, de l’institution financière ou de l’autre personne qui détient ces
biens.
2. Le ou les numéros de compte associés au conseiller, au courtier, à l’institution financière ou à l’autre personne en ce
qui concerne ces biens.
3. La valeur totale de tous les biens détenus dans chacun des comptes visés à la disposition 2.
Obligation de mise à jour des renseignements : déclaration modifiée
4. (1) S’il s’aperçoit qu’un renseignement visé à la disposition 5, 6 ou 14 du paragraphe 3 (2) ou au paragraphe 3 (3) qui
a été donné dans la déclaration est inexact ou incomplet, le représentant successoral remet au ministre une déclaration révisée
contenant le renseignement à jour et indiquant la raison de la mise à jour.
(2) La déclaration révisée prévue au paragraphe (1) doit être remise au plus tard 30 jours après que le représentant
successoral s’est aperçu que le renseignement donné est inexact ou incomplet.
153
174
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
(3) La déclaration révisée prévue au paragraphe (1) n’est pas obligatoire si le représentant successoral s’aperçoit que le
renseignement est inexact ou incomplet après le quatrième anniversaire du jour où l’impôt est devenu exigible.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si une déclaration portant que des biens de la succession ont été découverts par
la suite est remise en application du paragraphe 32 (2) de la Loi sur les successions, le représentant successoral remet au
ministre, au plus tard 30 jours après la remise de la déclaration, une déclaration révisée donnant des précisions au sujet de ces
biens.
Obligation de mise à jour des renseignements : avis au ministre
5. S’il s’aperçoit qu’un renseignement visé à la disposition 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 du paragraphe 3 (2) qui a été
donné dans la déclaration est inexact ou incomplet, le représentant successoral avise par écrit le ministre du renseignement à
jour au plus tard 30 jours après s’être aperçu que le renseignement est inexact ou incomplet.
Renseignements supplémentaires : remboursement reçu
6. Si, après avoir remis la déclaration visée à l’article 3, le représentant successoral reçoit un remboursement total ou
partiel du dépôt ou de l’impôt fixé par la Loi, il remet au ministre, au plus tard 30 jours après avoir reçu le remboursement,
une déclaration révisée donnant des précisions au sujet du remboursement.
Renseignements supplémentaires : impôt ou dépôt supplémentaire
7. Si, après avoir remis la déclaration visée à l’article 3, le représentant successoral paie un impôt supplémentaire fixé par
la Loi ou dépose un montant supplémentaire, il remet au ministre, au plus tard 30 jours après le paiement ou le dépôt, une
déclaration révisée donnant des précisions au sujet du paiement ou du dépôt.
Renseignements supplémentaires : engagement prévu au par. 4 (3) de la Loi
8. S’il remet l’engagement prévu au paragraphe 4 (3) de la Loi à l’égard de la succession du défunt, le représentant
successoral remet au ministre, au plus tard 30 jours après avoir exécuté l’engagement, une déclaration révisée donnant des
précisions au sujet de l’exécution et de tout impôt supplémentaire payé.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: December 22, 2014.
Pris le : 22 décembre 2014.
2/15
154
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO175
ONTARIO REGULATION 311/14
made under the
HIGHWAY TRAFFIC ACT
Made: December 16, 2014
Filed: December 23, 2014
Published on e-Laws: December 23, 2014
Printed in The Ontario Gazette: January 10, 2015
Amending Reg. 598 of R.R.O. 1990
(GROSS WEIGHT ON BRIDGES)
1. Sections 1 and 2 of Regulation 598 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 are revoked and the following
substituted:
1. No person shall move a vehicle or combination of vehicles of a class described in Column 1 of the Table in a Schedule
to this Regulation on, over or upon the bridge described in the Schedule if the gross weight of the vehicle or combination of
vehicles is greater than the weight in tonnes set opposite in Column 2 of the Table in the Schedule.
2. Schedules 1, 2, 3.2, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 22 and 24 to 27 to the Regulation are revoked and the following substituted:
SCHEDULE 1
BRIDGE NO. 9-2
GRAND RIVER CONCRETE BOW STRING BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 9-2, known as the Grand River Concrete Bow String Bridge, located on Argyle Street South, formerly part of the
King’s Highway known as No. 6, in the County of Haldimand, formerly Town of Caledonia, over the Grand River.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in
Tonnes
15 tonnes
27 tonnes
37 tonnes
SCHEDULE 2
BRIDGE NO. 41S-24
GULLWING CREEK BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 41S-24, known as the Gullwing Creek Bridge, located on Henderson Loop North, Lot 6, Concessions 2 and 3,
Britton Local Roads Board in the District of Kenora, over the Gullwing Creek.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
21 tonnes
38 tonnes
50 tonnes
155
176
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
SCHEDULE 3
BRIDGE NO. 41S-25
GULLWING CREEK BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 41S-25, known as the Gullwing Creek Bridge, located on Henderson Loop South, Lot 6, Concession 1, Britton
Local Roads Board in the District of Kenora, over the Gullwing Creek.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
21 tonnes
38 tonnes
50 tonnes
SCHEDULE 4
BRIDGE NO. 45-122
FOOTPRINT RIVER BAILEY BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 45-122, known as the Footprint River Bailey Bridge, on that part of the King’s Highway known as No. 613, in
the District of Rainy River, over the Footprint River.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
22 tonnes
39 tonnes
54 tonnes
SCHEDULE 5
BRIDGE NO. 45-131
OTTERTAIL RIVER BAILEY BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 45-131, known as the Ottertail River Bailey Bridge, on Pearson Landing Road, Lot 7, Concession 6, Pearson
Landing Local Roads Board in the District of Rainy River, over the Ottertail River.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
11 tonnes
19 tonnes
29 tonnes
SCHEDULE 6
BRIDGE NO. 47-085
ROSEGROVE ROAD BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 47-085, known as the Rosegrove Road Bridge, located approximately 3.5 kilometres east of the King’s Highway
known as No. 11 on Rosegrove Road in the geographic Township of Otto, in the District of Timiskaming, over the Blanche
River.
156
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO177
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
9 tonnes
16 tonnes
23 tonnes
SCHEDULE 7
BRIDGE NO. 48C-94
SIBLEY CREEK BRIDGE
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 48C-94, known as the Sibley Creek Bridge, on that part of the King’s Highway known as No. 587, in the
geographic Township of Sibley in the District of Thunder Bay, over the Sibley Creek.
TABLE
Column 1
Vehicle
All vehicles and combinations
of vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
3 tonnes
SCHEDULE 8
BRIDGE NO. 48W-24
SUNSHINE CREEK BAILEY BRIDGE NO. 2
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 48W-24, known as the Sunshine Creek Bailey Bridge No. 2, located on Ellis Road, Dawson-Goldie Local Roads
Board in the District of Thunder Bay, over the Sunshine Creek.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
13 tonnes
21 tonnes
32 tonnes
SCHEDULE 9
BRIDGE NO. 48W-71
WHITEFISH RIVER BAILEY BRIDGE NO. 1
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 48W-71, known as the Whitefish River Bailey Bridge No. 1, located on Niemi Road, Lot 3, Concession 5, Strange
Local Roads Board in the District of Thunder Bay, over the North Whitefish River.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
14 tonnes
23 tonnes
34 tonnes
157
178
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
SCHEDULE 10
BRIDGE NO. 48W-72
WHITEFISH RIVER BAILEY BRIDGE NO. 2
DESCRIPTION OF BRIDGE
Bridge No. 48W-72, known as the Whitefish River Bailey Bridge No. 2. located on Pykari Road, Lot 2, Concession 6,
Strange Local Roads Board in the District of Thunder Bay, over the North Whitefish River.
TABLE
Column 1
Vehicle
single vehicle
single vehicle with one towed
vehicle
single vehicle with two towed
vehicles
Column 2
Gross Weight Limit in Tonnes
18 tonnes
33 tonnes
46 tonnes
Commencement
3. This Regulation comes into force on the day it is filed.
Made by:
Steven Del Duca
Minister of Transportation
Date made: December 16, 2014.
2/15
158
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO179
ONTARIO REGULATION 312/14
made under the
FARM PRODUCTS MARKETING ACT
Made: November 19, 2014
Approved: December 18, 2014
Filed: December 23, 2014
Published on e-Laws: December 23, 2014
Printed in The Ontario Gazette: January 10, 2015
Amending O. Reg. 484/09
(GRAIN (GRAIN CORN, SOYBEANS AND WHEAT) - PLAN)
1. Subsections 9 (2) to (6) of Ontario Regulation 484/09 are revoked and the following substituted:
(2) The local board shall appoint a board member for a district within seven days after the board’s first meeting following
an election if,
(a) the District Grain Committee for a district fails to elect a board member on or before March 1; or
(b) the District Grain Committee for a district notifies the local board in writing on or before March 1 that it is unable to
elect a board member.
(3) The local board may hold its first meeting after an election at any time after each district has either elected a board
member or informed the local board that it is unable to elect a board member, but in any case the local board shall hold its
first meeting on or before March 16.
(4) If the members of the local board do not appoint a board member for a district under subsection (2), the Commission
may appoint a board member for the district within 30 days after the end of the time period set out in subsection (2).
(5) A new board member takes office on the day of the first board meeting that is held after the member’s election or
appointment and, subject to subsections (6) and (7), holds office until the day before the first board meeting after the elections
in the second year following the year of the member’s election or appointment.
(6) Board members elected in 2014 by the District Grain Committees for Districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 shall hold
office only until the day before the first board meeting that is held after the elections in 2015.
(7) If a delegate to a District Grain Committee is elected to the local board under this section or is appointed under this
section or section 11 and subsequently resigns as delegate to the Committee before his or her term as board member ends
under subsection (5) or (6), his or her term as a board member ends on the day the resignation as delegate to the Committee
becomes effective. 159
180
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Commencement
2. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2015 and the day it is filed.
Made by:
Pris par :
Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :
Geri Kamenz
Chair
Mike Relf
Secretary to the Commission
Date made: November 19, 2014.
Pris le : 19 novembre 2014.
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Jeff Leal
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs
Date approved: December 18, 2014.
Approuvé le : 18 décembre 2014.
2/15
160
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO181
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/14
pris en vertu de la
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
pris le 19 novembre 2014
approuvé le 18 décembre 2014
déposé le 23 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 10 janvier 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 484/09
GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) - PLAN)
1. Les paragraphes 9 (2) à (6) du Règlement de l’Ontario 484/09 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) La commission locale nomme elle-même l’un de ses membres pour un district dans les sept jours qui suivent sa
première réunion suivant une élection si, selon le cas :
a) les membres du comité de district pour un district n’élisent pas un membre de la commission locale au plus tard le 1er
mars;
b) au plus tard le 1er mars, les membres du comité de district pour un district avisent la commission locale par écrit qu’ils
sont incapables d’élire un membre de celle-ci.
(3) La commission locale peut tenir sa première réunion suivant une élection à tout moment après que chaque district a élu
un membre de la commission locale ou a avisé celle-ci qu’il est incapable de l’élire. Dans tous les cas, la commission locale
doit tenir sa première réunion au plus tard le 16 mars.
(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un membre de celle-ci pour un district aux termes du
paragraphe (2), la Commission peut le faire dans les 30 jours suivant la fin du délai prévu à ce paragraphe.
(5) Les nouveaux membres de la commission locale entrent en fonction le jour de la première réunion de celle-ci qui
suit leur élection ou leur nomination. Sous réserve des paragraphes (6) et (7), ils exercent leur mandat jusqu’à la veille de la
première réunion de la commission locale qui suit les élections tenues la deuxième année suivant celle de leur élection ou
nomination.
(6) Les membres de la commission locale élus en 2014 par les comités de district pour les districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et
15 exercent leur mandat jusqu’à la veille de la première réunion de la commission locale qui suit les élections de 2015.
(7) Si un délégué au comité de district est élu à la commission locale en vertu du présent article ou nommé à celle-ci aux
termes du présent article ou de l’article 11 et qu’il démissionne par la suite de son poste de délégué avant que son mandat
comme membre de la commission locale se termine en application du paragraphe (5) ou (6), ce mandat se termine le jour où
sa démission prend effet.
161
182
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :
Geri Kamenz
Chair
Mike Relf
Secretary to the Commission
Date made: November 19, 2014.
Pris le : 19 novembre 2014.
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Jeff Leal
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs
Date approved: December 18, 2014.
Approuvé le : 18 décembre 2014.
2/15
NOTE: Consolidated regulations and various legislative tables pertaining to regulations can be found on the e-Laws website
(www.e-Laws.gov.on.ca).
REMARQUE : Les règlements codifiés et diverses tables concernant les règlements se trouvent sur le site Lois-en-ligne
(www.lois-en-ligne.gouv.on.ca).
162
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
183
INDEX 02
Parliamentary Notice........................................................................................................................................................................................................................161
Avis parlementaire........................................................................................................................................................................................................................161
Criminal Code...................................................................................................................................................................................................................................162
Code Criminel..............................................................................................................................................................................................................................162
Ontario Highway Transport Board....................................................................................................................................................................................................163
Government Notices Respecting Corporations.................................................................................................................................................................................163
Avis du gouvernement relatifs aux compagnies...........................................................................................................................................................................163
Notice of Default in Complying with the Corporations Tax Act......................................................................................................................................................163
Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés.................................................................................................................................................163
Cancellation of Certificate of Incorporation (Corporations Tax Act Defaulters)..............................................................................................................................164
Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)...........................................................................................164
Certificate of Dissolution..................................................................................................................................................................................................................165
Certificat de dissolution................................................................................................................................................................................................................165
Foreign Cultural Objects Immunity from Seizure Act Determination..............................................................................................................................................167
Applications to Provincial Parliament — Private Bills....................................................................................................................................................................167
Demandes au Parlement provincial — Projets de loi d’intérêt privé...........................................................................................................................................167
Corporation Notices..........................................................................................................................................................................................................................167
Avis relatifs aux compagnies........................................................................................................................................................................................................167
PUBLICATIONS UNDER PART III (REGULATIONS) OF THE LEGISLATION ACT, 2006
RÈGLEMENTS PUBLIÉS EN APPLICATION DE LA PARTIE III (RÈGLEMENTS) DE LA LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION..............................169
ESTATE ADMINISTRATION TAX ACT, 1998
FARM PRODUCTS MARKETING ACT
HIGHWAY TRAFFIC ACT
O. Reg. 310/14.........................................................................169
O. Reg. 312/14.........................................................................179
O. Reg. 311/14.........................................................................175
Texte d’information pour la Gazette de l’Ontario.............................................................................................................................................................................185
Information Text for Ontario Gazette...............................................................................................................................................................................................186
This page intentionally left blank
Cette page est volontairement laissée en blanc
This page intentionally left blank
Cette page est volontairement laissée en blanc
This page intentionally left blank
Cette page est volontairement laissée en blanc
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO187
Texte d’information pour la Gazette de l’Ontario
La Gazette de l’Ontario paraît chaque samedi, et les annonces à y insérer doivent parvenir à ses bureaux le jeudi à 15h au plus tard, soit au
moins neuf jours avant la parution du numéro dans lequel elles figureront. Pour les semaines incluant le lundi de Pâques, le 11 novembre et
les congés statutaires, accordez une journée de surplus. Pour connaître l’horaire entre Noël et le Jour de l’An s’il vous plaît communiquez
avec le bureau de La Gazette de l’Ontario au (416) 326-5310 ou par courriel à [email protected]
Tarifs publicitaires et soumission de format :
1) Envoyer les annonces dans le format Word.doc par courriel à [email protected]
2) Le tarif publicitaire pour la première insertion envoyée électroniquement est de 75,00$ par espace-colonne jusqu’à un ¼ de page.
3) Pour chaque insertion supplémentaire commandée en même temps que l’insertion initiale, le tarif est 40,00$
4) Les clients peuvent confirmer la publication d’une annonce en visitant le site web de La Gazette de l’Ontario
www.ontario.ca/gazette ou en visionnant une copie imprimée à une bibliothèque locale.
Abonnement :
Le tarif d’abonnement annuel est de 126,50$ + T.V.H. pour 52 ou 53 numéros hebdomadaires débutant le premier samedi du mois de
janvier (payable à l’avance) L’inscription d’un nouvel abonnement au courant de l’année sera calculée de façon proportionnelle pour la
première année. Un nouvel abonné peut commander des copies d’éditions précédentes de la Gazette au coût d’une copie individuelle si
l’inventaire le permet.
Le remboursement pour l’annulation d’abonnement sera calculé de façon proportionnelle à partir de 50% ou moins selon la date. Pour
obtenir de l’information sur l’abonnement ou les commandes s.v.p. téléphonez le (416) 326-5306 durant les heures de bureau.
Copies individuelles :
Des copies individuelles de la Gazette peuvent être commandées en direct en ligne au site www.serviceontario.ca/publications ou en
téléphonant 1-800-668-9938.
Options de paiement :
Les paiements peuvent être effectués au moyen de la carte Visa, MasterCard ou Amex, ou chèques ou mandats fait à l’ordre du MINISTRE
DES FINANCES. Toute correspondance, notamment les changements d’adresse, doit être adressée à :
LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Direction de la gestion des revenus
Publications Ontario
222, rue Jarvis, 8ème étage, Toronto, Ontario M7A 0B6
Téléphone (416) 326-5306
Paiement – Annonces :
Pour le traitement rapide les clients peuvent faire leur paiement au moyen de la carte Visa, MasterCard ou Amex lorsqu’ils soumettrent
leurs annonces. Les frais peuvent également être facturés.
MINISTÈRES DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO S.V.P. NOTEZ
Paiements par écriture de journal seulement. S.V.P. communiquez avec le bureau de la Gazette au 416 326-5310
ou à [email protected]
188
THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO
Information Text for Ontario Gazette
The Ontario Gazette is published every Saturday. Advertisements/notices must be received no later than 3 pm on Thursday, 9 days before
publication of the issue in which they should appear. For weeks including Easter Monday, November 11th or a statutory holiday allow an
extra day. For the Christmas/New Year holiday schedule please contact the Gazette at (416) 326-5310 or by email at
[email protected]
Advertising rates and submission formats:
1) Please submit all notices in a Word.doc format to: [email protected]
2) For a first insertion electronically submitted the basic rate is $75 up to ¼ page.
3) For subsequent insertions of the same notice ordered at the same time the rate is $40 each.
4) Clients may confirm publication of a notice by visiting The Ontario Gazette web site at: www.ontario.ca/gazette or by viewing a
printed copy at a local library.
Subscriptions:
The annual subscription rate is $126.50 + H.S.T. for 52 or 53 weekly issues beginning the first Saturday in January, payable in advance.
In-year new subscriptions will be pro-rated for the first year. A new subscriber may order back issues of the Gazette at the single-copy rate
as inventory permits.
Refunds for cancelled subscriptions will be pro-rated from 50% or less depending upon date. For subscription information/orders please
call (416) 326-5306 during normal business hours.
Single Copies:
Individual Gazette copies may be ordered on-line through the website at www.serviceontario.ca/publications or by phone at
1-800-668-9938.
Payment Options:
Subscriptions may be paid by VISA, AMEX or MasterCard or by Cheque or Money order payable to THE MINISTER OF FINANCE. All
subscription enquiries and correspondence, including address changes, should be mailed to:
THE ONTARIO GAZETTE
Publications Ontario Financial Unit
222 Jarvis Street, 8th Floor, Toronto, Ontario M7A 0B6
Telephone: (416) 326-5306
Payment – Notices:
For fastest processing clients may pay by VISA, AMEX or MasterCard when submitting notices. Charges may also be invoiced.
ONTARIO GOVERNMENT MINISTRIES PLEASE NOTE:
Payment by Journal Entry only. Please contact the Gazette office at 416 326-5310
or at [email protected]